National Register of Historic Places in Kentucky

Diese Tabelle enthält a​lle Listen, i​n denen d​ie Einträge i​m National Register of Historic Places i​n den 120 Countys d​es US-amerikanischen Bundesstaates Kentucky aufgeführt sind[1]:

Karte der Countys von Kentucky und Verteilung der NRHP-Einträge

Anzahl der Objekte und Distrikte nach County

Das Kentucky State Capitol in Frankfort, seit 1973 im NRHP gelistet[2]
Die Southern National Bank in Louisville, seit 1971 im NRHP gelistet[3]
Churchill Downs in Louisville, der Austragungsort des jährlichen Kentucky Derby; seit 1978 im NRHP gelistet[4]
Das Henry Clay Monument in Lexington, seit 1976 im NRHP gelistet[5]
County Liste der Einträge in das NRHP im County Anzahl
1 Adair NRHP-Einträge im Adair County 9
2 Allen NRHP-Einträge im Allen County 11
3 Anderson NRHP-Einträge im Anderson County 12
4 Ballard NRHP-Einträge im Ballard County 6
5 Barren NRHP-Einträge im Barren County 34
6 Bath NRHP-Einträge im Bath County 8
7 Bell NRHP-Einträge im Bell County 9
8 Boone NRHP-Einträge im Boone County 106
9 Bourbon NRHP-Einträge im Bourbon County 60
10 Boyd NRHP-Einträge im Boyd County 26
11 Boyle NRHP-Einträge im Boyle County 92
12 Bracken NRHP-Einträge im Bracken County 22
13 Breathitt NRHP-Einträge im Breathitt County 7
14 Breckinridge NRHP-Einträge im Breckinridge County 11
15 Bullitt NRHP-Einträge im Bullitt County 9
16 Butler NRHP-Einträge im Butler County 17
17 Caldwell NRHP-Einträge im Caldwell County 9
18 Calloway NRHP-Einträge im Calloway County 16
19 Campbell NRHP-Einträge im Campbell County 58
20 Carlisle NRHP-Einträge im Carlisle County 5
21 Carroll NRHP-Einträge im Carroll County 11
22 Carter NRHP-Einträge im Carter County 4
23 Casey NRHP-Einträge im Casey County 2
24 Christian NRHP-Einträge im Christian County 47
25 Clark NRHP-Einträge im Clark County 66
26 Clay NRHP-Einträge im Clay County 3
27 Clinton NRHP-Einträge im Clinton County 2
28 Crittenden NRHP-Einträge im Crittenden County 3
29 Cumberland NRHP-Einträge im Cumberland County 3
30 Daviess NRHP-Einträge im Daviess County 35
31 Edmonson NRHP-Einträge im Edmonson County 23
32 Elliott NRHP-Einträge im Elliott County 1
33 Estill NRHP-Einträge im Estill County 8
34 Fayette NRHP-Einträge im Fayette County 168
35 Fleming NRHP-Einträge im Fleming County 11
36 Floyd NRHP-Einträge im Floyd County 15
37 Franklin NRHP-Einträge im Franklin County 51
38 Fulton NRHP-Einträge im Fulton County 16
39 Gallatin NRHP-Einträge im Gallatin County 4
40 Garrard NRHP-Einträge im Garrard County 66
41 Grant NRHP-Einträge im Grant County 2
42 Graves NRHP-Einträge im Graves County 10
43 Grayson NRHP-Einträge im Grayson County 11
44 Green NRHP-Einträge im Green County 46
45 Greenup NRHP-Einträge im Greenup County 20
46 Hancock NRHP-Einträge im Hancock County 12
47 Hardin NRHP-Einträge im Hardin County 90
48 Harlan NRHP-Einträge im Harlan County 5
49 Harrison NRHP-Einträge im Harrison County 25
50 Hart NRHP-Einträge im Hart County 18
51 Henderson NRHP-Einträge im Henderson County 27
52 Henry NRHP-Einträge im Henry County 11
53 Hickman NRHP-Einträge im Hickman County 4
54 Hopkins NRHP-Einträge im Hopkins County 31
55 Jackson NRHP-Einträge im Jackson County 5
56 Jefferson NRHP-Einträge im Jefferson County 466
57 Jessamine NRHP-Einträge im Jessamine County 72
58 Johnson NRHP-Einträge im Johnson County 39
59 Kenton NRHP-Einträge im Kenton County 59
60 Knott NRHP-Einträge im Knott County 2
61 Knox NRHP-Einträge im Knox County 8
62 LaRue NRHP-Einträge im LaRue County 31
63 Laurel NRHP-Einträge im Laurel County 8
64 Lawrence NRHP-Einträge im Lawrence County 10
65 Lee NRHP-Einträge im Lee County 9
66 Leslie NRHP-Einträge im Leslie County 5
67 Letcher NRHP-Einträge im Letcher County 3
68 Lewis NRHP-Einträge im Lewis County 5
69 Lincoln NRHP-Einträge im Lincoln County 22
70 Livingston NRHP-Einträge im Livingston County 7
71 Logan NRHP-Einträge im Logan County 22
72 Lyon NRHP-Einträge im Lyon County 4
73 Madison NRHP-Einträge im Madison County 77
74 Magoffin NRHP-Einträge im Magoffin County 2
75 Marion NRHP-Einträge im Marion County 10
76 Marshall NRHP-Einträge im Marshall County 5
77 Martin NRHP-Einträge im Martin County 2
78 Mason NRHP-Einträge im Mason County 36
79 McCracken NRHP-Einträge im McCracken County 27
80 McCreary NRHP-Einträge im McCreary County 2
81 McLean NRHP-Einträge im McLean County 9
82 Meade NRHP-Einträge im Meade County 13
83 Menifee NRHP-Einträge im Menifee County 6
84 Mercer NRHP-Einträge im Mercer County 71
85 Metcalfe NRHP-Einträge im Metcalfe County 4
86 Monroe NRHP-Einträge im Monroe County 6
87 Montgomery NRHP-Einträge im Montgomery County 18
88 Morgan NRHP-Einträge im Morgan County 9
89 Muhlenberg NRHP-Einträge im Muhlenberg County 11
90 Nelson NRHP-Einträge im Nelson County 41
91 Nicholas NRHP-Einträge im Nicholas County 12
92 Ohio NRHP-Einträge im Ohio County 18
93 Oldham NRHP-Einträge im Oldham County 46
94 Owen NRHP-Einträge im Owen County 17
95 Owsley NRHP-Einträge im Owsley County 1
96 Pendleton NRHP-Einträge im Pendleton County 20
97 Perry NRHP-Einträge im Perry County 1
98 Pike NRHP-Einträge im Pike County 15
99 Powell NRHP-Einträge im Powell County 16
100 Pulaski NRHP-Einträge im Pulaski County 39
101 Robertson NRHP-Einträge im Robertson County 3
102 Rockcastle NRHP-Einträge im Rockcastle County 3
103 Rowan NRHP-Einträge im Rowan County 12
104 Russell NRHP-Einträge im Russell County 1
105 Scott NRHP-Einträge im Scott County 81
106 Shelby NRHP-Einträge im Shelby County 137
107 Simpson NRHP-Einträge im Simpson County 14
108 Spencer NRHP-Einträge im Spencer County 13
109 Taylor NRHP-Einträge im Taylor County 14
110 Todd NRHP-Einträge im Todd County 15
111 Trigg NRHP-Einträge im Trigg County 8
112 Trimble NRHP-Einträge im Trimble County 27
113 Union NRHP-Einträge im Union County 7
114 Warren NRHP-Einträge im Warren County 96
115 Washington NRHP-Einträge im Washington County 67
116 Wayne NRHP-Einträge im Wayne County 7
117 Webster NRHP-Einträge im Webster County 3
118 Whitley NRHP-Einträge im Whitley County 12
119 Wolfe NRHP-Einträge im Wolfe County 3
120 Woodford NRHP-Einträge im Woodford County 81
Summe3.2931
Das Union Monument in Perryville, seit 1997 im NRHP gelistet[6]
Das Confederate Monument in Danville, seit 1997 im NRHP gelistet[7]
Das Union County Courthouse in Morganfield, seit 1978 im NRHP gelistet[8]
1 Einige der Objekte könnten aufgrund ihrer Lage und Ausdehnung in mehreren Listen verzeichnet sein, weshalb die Summe nicht exakt sein könnte.

Siehe auch

Einzelnachweise

  1. National Register of Historic Places Abgerufen am 7. September 2012
  2. Auszug aus dem National Register of Historic Places - Nr. 73000804 Abgerufen am 7. September 2012
  3. Auszug aus dem National Register of Historic Places - Nr. 71000349 Abgerufen am 7. September 2012
  4. Auszug aus dem National Register of Historic Places - Nr. 78001348 Abgerufen am 7. September 2012
  5. Auszug aus dem National Register of Historic Places - Nr. 76000873 Abgerufen am 7. September 2012
  6. Auszug aus dem National Register of Historic Places - Nr. 97000723 Abgerufen am 7. September 2012
  7. Auszug aus dem National Register of Historic Places - Nr. 97000720 Abgerufen am 7. September 2012
  8. Auszug aus dem National Register of Historic Places - Nr. 78001401 Abgerufen am 7. September 2012
Commons: National Register of Historic Places in Kentucky – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. The authors of the article are listed here. Additional terms may apply for the media files, click on images to show image meta data.