Liste der Einträge im National Register of Historic Places im Wyoming County (New York)

Diese Liste d​er Einträge i​m National Register o​f Historic Places i​n Wyoming County, New York enthält a​lle bis z​um Stichtag ausgewiesenen Anwesen u​nd Distrikte, d​ie im Wyoming County i​n New York i​n das National Register o​f Historic Places aufgenommen wurden.

Stand: 21. April 2017
Lage des Wyoming Countys in New York

Liste der Einträge

[1] Name Bild Eintragsdatum Lage Ort Beschreibung
1 Arcade and Attica Railroad
Arcade and Attica Railroad
17. Nov. 1980
ID-Nr. 80002797
Railroad Right of way von Arcade nach North Java
42° 34′ 24″ N, 78° 25′ 22″ W
North Java
2 Arcade Center Farm 15. Apr. 2004
ID-Nr. 04000290
7298 NY 98
42° 32′ 38″ N, 78° 24′ 12″ W
Arcade
3 Attica Market and Main Historic District
Attica Market and Main Historic District
1. Mai 2013
ID-Nr. 13000225
2-28 & 19-45 Market St., 2-10 & 21-39 Main St.
42° 51′ 54,7″ N, 78° 17′ 4,8″ W
Attica
4 Brick Presbyterian Church
Brick Presbyterian Church
3. Okt. 2007
ID-Nr. 07001042
6 Church St.
42° 43′ 15″ N, 78° 0′ 4,7″ W
Perry
5 Epworth Hall
Epworth Hall
6. Apr. 2000
ID-Nr. 00000350
Perry Ave.
42° 41′ 53″ N, 78° 1′ 16″ W
Perry
6 Exchange Street Historic District
Exchange Street Historic District
21. Nov. 2012
ID-Nr. 12000962
15-48 Exchange St. & Erie RR Depot
42° 51′ 47,6″ N, 78° 16′ 49,7″ W
Attica
7 First Free Will Baptist Church of Pike
First Free Will Baptist Church of Pike
27. Juni 2012
ID-Nr. 12000369
72 Main St.
42° 33′ 16,6″ N, 78° 9′ 21″ W
Pike
8 First Methodist Episcopal Church of Perry
First Methodist Episcopal Church of Perry
28. Sep. 2006
ID-Nr. 06000880
35 Covington St.
42° 43′ 10″ N, 78° 0′ 18″ W
Perry
9 First Universalist Church of Portageville
First Universalist Church of Portageville
19. Feb. 2008
ID-Nr. 08000040
E. Koy Rd. at NY 19A
42° 34′ 4″ N, 78° 2′ 43″ W
Portageville
10 Bryant Fleming House
Bryant Fleming House
14. Okt. 2009
ID-Nr. 09000838
1024 Tower Road
42° 49′ 52,4″ N, 78° 5′ 30,7″ W
Wyoming
11 Seth M. Gates House
Seth M. Gates House
21. Feb. 1992
ID-Nr. 92000031
15 Perry Ave.
42° 44′ 26″ N, 78° 8′ 6″ W
Warsaw
12 Java School No. 1 21. Juni 2001
ID-Nr. 01000672
NY 78
42° 40′ 26″ N, 78° 26′ 11″ W
Java Village
13 Letchworth State Park
Letchworth State Park
4. Nov. 2005
ID-Nr. 03000718
Genesee River Gorge zwischen Portageville und Mt. Morris
42° 38′ 5″ N, 77° 59′ 0″ W
Castile
14 Middlebury Academy
Middlebury Academy
17. Jan. 1973
ID-Nr. 73001293
22 S. Academy St.
42° 49′ 39″ N, 78° 5′ 23″ W
Wyoming
15 Monument Circle Historic District
Monument Circle Historic District

weitere Bilder
11. Mai 1992
ID-Nr. 92000447
grob entlang der E. Court St. zwischen N. Main St. und Park St. sowie die angrenzenden Teile von Main und Park St.
42° 44′ 35″ N, 78° 7′ 53″ W
Warsaw
16 Perry Downtown Historic District
Perry Downtown Historic District
16. Apr. 2012
ID-Nr. 12000212
N. & S. Main, Covington, & Lake Sts., Borden Ave.
42° 43′ 6,3″ N, 78° 0′ 7,4″ W
Perry
17 Barna C. Roup House 10. Aug. 2015
ID-Nr. 15000519
38 Borden Ave.
42° 43′ 2,4″ N, 78° 0′ 11,9″ W
Perry 1898 im Queen Anne Style errichtetes Haus eines örtlich bekannten Rechtsanwaltes aus der Zeit des großen Wachstums des Villages
18 Silver Lake Institute Historic District
Silver Lake Institute Historic District
19. Sep. 1985
ID-Nr. 85002442
grob begrenzt durch Wesley, Embury, Thompson, Haven, Lakeside und Lakeview Aves.
42° 41′ 56″ N, 78° 1′ 20″ W
Silver Lake
19 Augustus A. Smith House
Augustus A. Smith House
27. Juni 2007
ID-Nr. 07000627
125 Main St.
42° 51′ 44″ N, 78° 16′ 42″ W
Attica
20 Trinity Church
Trinity Church
18. März 1980
ID-Nr. 80002798
W. Buffalo St.
42° 44′ 23″ N, 78° 8′ 3″ W
Warsaw
21 US Post Office-Attica
US Post Office-Attica
17. Nov. 1988
ID-Nr. 88002453
76 Main St.
42° 51′ 49″ N, 78° 16′ 51″ W
Attica
22 US Post Office-Warsaw
US Post Office-Warsaw

weitere Bilder
11. Mai 1989
ID-Nr. 88002441
35 S. Main St.
42° 44′ 22″ N, 78° 7′ 59″ W
Warsaw
23 Warsaw Academy
Warsaw Academy
3. Jan. 1980
ID-Nr. 80002799
73 S. Main St.
42° 44′ 19″ N, 78° 7′ 58″ W
Warsaw
24 Warsaw Downtown Historic District
Warsaw Downtown Historic District
21. Nov. 2012
ID-Nr. 12000963
N. & S. Main zwischen Frank & Brooklyn Sts.
42° 44′ 21,9″ N, 78° 7′ 57,3″ W
Warsaw
25 Orator F. Woodward Cottage 22. Aug. 2016
ID-Nr. 16000559
3931 Thompson Ave.
42° 41′ 54,8″ N, 78° 1′ 10,8″ W
Silver Lake 1894 erbautes Ferienhaus des Jell-O-Erfinders, das später als Gästehaus für methodistische Prediger genutzt wurde, die das Silver Lake Institute besuchten
26 Wyoming Village Historic District
Wyoming Village Historic District
27. Dez. 1974
ID-Nr. 74001326
NY 19
42° 49′ 37″ N, 78° 5′ 15″ W
Wyoming

Siehe auch

Commons: National Register of Historic Places in Wyoming County, New York – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

Anmerkungen

  1. Die Nummerierung in dieser Listenspalte ist an der vom National Park Service vorgelegten Reihenfolge der Einträge orientiert; die Farben unterscheiden verschiedene Schutzgebietstypen des National Park Systems mit landesweiter Bedeutung (z. B. National Historic Landmarks) von den sonstigen Einträgen im National Register of Historic Places.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. The authors of the article are listed here. Additional terms may apply for the media files, click on images to show image meta data.